Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 3/1/2020 - Empresarios

Text version What is this?Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Empresarios

BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 2

Viernes 3 de enero de 2020

Pág. 83

642 - PARKING 347 SOCIEDAD LIMITADA.
Pérdida del caracter de unipersonalidad. Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: GUTIERREZ SAEZ JOSE LUIS. Nombramientos.
Adm. Unico: GUTIERREZ TEBAR DIEGO. Datos registrales. T 941, L 705, F 170, S 8, H AB 23972, I/A 2 24.12.19.
643 - PARKING 347 SOCIEDAD LIMITADA.
Nombramientos. Apoderado: GUTIERREZ SAEZ JOSE LUIS. Datos registrales. T 1014, L 778, F 43, S 8, H AB 23972, I/A 3
24.12.19.
644 - ACTUA NOVA URBANA SOCIEDAD LIMITADA EN LIQUIDACION.
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: MUÑOZ MEDRANO PEDRO;ROLDAN ARAEZ ANTONIO. Nombramientos. Liquidador M:
ROLDAN ARAEZ ANTONIO;JIMENEZ GOMEZ ROSARIO. Cambio de domicilio social. C/ BLASCO DE GARAY, 20 bajo 02003
ALBACETE. Disolución. Voluntaria. Datos registrales. T 962, L 726, F 116, S 8, H AB 25122, I/A 2 24.12.19.
645 - LANAS Y OVINOS PARREÑO SOCIEDAD LIMITADA.
Ceses/Dimisiones. Liquidador: CARRASCO GOMEZ MARIA NIEVES. Adm. Unico: CARRASCO GOMEZ MARIA NIEVES.
Nombramientos. Liquidador: CARRASCO GOMEZ MARIA NIEVES. Disolución. Voluntaria. Extinción. Datos registrales. T 838, L 602, F 163, S 8, H AB 17301, I/A 4 24.12.19.
646 - AGRICOLA COVIRU SOCIEDAD LIMITADA.
Constitución. Comienzo de operaciones: 20.12.19. Objeto social: Explotación agrícola de cultivos perennes. -CNAES 0121 al 0129-.
Realización de trabajos a terceros relacionados con la agricultura y ganadería y prestación de servicios en general relacionados con la agricultura. -CNAE 0161-. - Actividades de intermediación en operaciones con valores y otros activ. Domicilio: C/ CARRASCA, 37 1º 02600 VILLARROBLEDO. Capital: 265.625,00 Euros. Nombramientos. Adm. Unico: VILLODRE RUS CONSTANCIO. Datos registrales. T 1014, L 778, F 46, S 8, H AB 27934, I/A 1 24.12.19.
647 - JAPEMA SPORT SOCIEDAD LIMITADA EN LIQUIDACION.
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: MARCO VERDEJO JAVIER JOSE. Nombramientos. Liquidador: MARCO VERDEJO JAVIER
JOSE. Disolución. Voluntaria. Datos registrales. T 976, L 740, F 178, S 8, H AB 25763, I/A 3 24.12.19.
648 - JAPEMA SPORT SOCIEDAD LIMITADA.
Ceses/Dimisiones. Liquidador: MARCO VERDEJO JAVIER JOSE. Extinción. Datos registrales. T 976, L 740, F 178, S 8, H AB
25763, I/A 4 24.12.19.
649 - TRANSPORTES MIGUEL LOPEZ TARAZONA SOCIEDAD LIMITADA.
Constitución. Comienzo de operaciones: 17.12.19. Objeto social: a.- El transporte público de mercancías por carretera, por cuenta propia y ajena, y subcontratación como organización auxiliar interpuesta entre quienes utilicen dicho servicio por carretera, agencia de transportes, y los concesionarios de servicios regulares o propietarios de vehículos autorizados. Domicilio: C/ CRUCES, 51 02100
TARAZONA DE LA MANCHA. Capital: 70.000,00 Euros. Nombramientos. Adm. Solid.: GONZALEZ MONTEAGUDO
MARIA;LOPEZ PICAZO MIGUEL. Datos registrales. T 1014, L 778, F 48, S 8, H AB 27935, I/A 1 26.12.19.
650 - SANTOS IBAÑEZ SOCIEDAD LIMITADA.
Nombramientos. Auditor: FOLCH RONCAL JORGE. Datos registrales. T 980, L 744, F 64, S 8, H AB 1131, I/A 19 26.12.19.
651 - GALERIAS BRINDIS SOCIEDAD LIMITADA.
Ceses/Dimisiones. Liquidador: GARCIA MARTINEZ JUAN. Adm. Unico: GARCIA MARTINEZ JUAN. Revocaciones. Apoderado:
GARCIA HERRAEZ ANTONIO. Nombramientos. Liquidador: GARCIA MARTINEZ JUAN. Disolución. Voluntaria. Extinción.
Datos registrales. T 894, L 658, F 66, S 8, H AB 1813, I/A 5 26.12.19.

653 - MAKING & SEWING SOCIEDAD LIMITADA.
Constitución. Comienzo de operaciones: 1.01.20. Objeto social: los trabajos y manufacturas sobre materiales textiles y otros materiales técnicos, para la industria. Domicilio: C/ ANTONIO MACHADO, 8 02611 OSSA DE MONTIEL. Capital: 15.000,00 Euros.
Declaración de unipersonalidad. Socio único: MORA VITORIA ANGEL. Nombramientos. Adm. Unico: MORA VITORIA ANGEL.
Datos registrales. T 1014, L 778, F 52, S 8, H AB 27936, I/A 1 26.12.19.
654 - ASECON PLANIFICACION SOCIEDAD LIMITADA.
Constitución. Comienzo de operaciones: 16.12.19. Objeto social: Servicio técnico de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico. A su actividad principal le corresponde el siguiente código: A la actividad principal que constituye el objeto social le corresponde en la CNAE - Clasificación Nacional de Actividades Económicasel número. Domicilio: C/ DOCTOR FERRAN, 3
7º izqu 02004 ALBACETE. Capital: 3.000,00 Euros. Nombramientos. Adm. Unico: CORDOBA OLIVARES PASCUAL FEDERICO.
Datos registrales. T 1014, L 778, F 54, S 8, H AB 27937, I/A 1 26.12.19.

cve: BORME-A-2020-2-02
Verificable en https www.boe.es
652 - ANFEJAMO SOCIEDAD LIMITADA.
Nombramientos. Auditor: FOLCH RONCAL JORGE. Datos registrales. T 986, L 750, F 52, S 8, H AB 7948, I/A 11 26.12.19.

About this edition

Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 3/1/2020 - Empresarios

TitleBoletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Empresarios

CountrySpain

Date03/01/2020

Page count205

Edition count3270

First edition03/01/2011

Last issue03/05/2024

Download this edition

Other editions

<<<Enero 2020>>>
DLMMJVS
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031