Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 13/1/2020 - Empresarios
Text version What is this?Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.
Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Empresarios
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 7
Lunes 13 de enero de 2020
Pág. 1001
SECCIÓN PRIMERA
Empresarios Actos inscritos ALBACETE
9146 - ALMANBROKER INMOBILIARIA 2012 SOCIEDAD LIMITADA.
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: SANCHEZ IGLESIAS GUILLERMO. Nombramientos. Adm. Unico: GONZALO AMOROS
GONZALO. Datos registrales. T 976, L 740, F 108, S 8, H AB 23073, I/A 5 3.01.20.
9147 - GRUPO ASESOR INMOBILIARIO JUSTICIA SOCIEDAD LIMITADA.
Constitución. Comienzo de operaciones: 25.11.19. Objeto social: Las actividades jurídicas; las actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoria y asesoría fiscal; las actividades inmobiliarias, por cuenta propia o de terceros; la gestión y administración de la propiedad inmobiliaria. Domicilio: C/ LA GILA, 30 HIGUERUELA. Capital: 21.404,00 Euros. Declaración de unipersonalidad. Socio único: MORATALLA SALIDO ALEJANDRO. Nombramientos. Adm. Unico: MORATALLA SALIDO ALEJANDRO. Datos registrales. T 1014, L 778, F 121, S 8, H AB 27965, I/A 1 2.01.20.
9148 - VULCAN ALMANSA SOCIEDAD LIMITADA.
Nombramientos. Auditor: MARTINEZ SOLER JESUS. Aud.Supl.: CHINCHILLA NUÑO DE LA ROSA FRANCISCO. Datos registrales. T 1012, L 776, F 154, S 8, H AB 24037, I/A 8 2.01.20.
9149 - PAÑALON SILO TANK SOCIEDAD LIMITADA.
Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 1013, L 777, F 35, S 8, H AB 27869, I/A 3
2.01.20.
9150 - SERVIAGRO AGROSERVICIOS VILLAROBLEDO SOCIEDAD LIMITADA.
Ampliación de capital. Capital: 98.564,00 Euros. Resultante Suscrito: 399.064,00 Euros. Datos registrales. T 921, L 685, F 116, S
8, H AB 7901, I/A 8 2.01.20.
9151 - ABONOS Y DERIVADOS LOS POCEROS SOCIEDAD LIMITADA.
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: ORTIZ ROMERA JESUS. Nombramientos. Adm. Solid.: ORTIZ CABALLERO PEDRO.
Ampliación de capital. Capital: 94.958,00 Euros. Resultante Suscrito: 401.468,00 Euros. Datos registrales. T 913, L 677, F 71, S 8, H AB 5015, I/A 8 2.01.20.
9152 - BESTETIC SELECTION MIRIAM COLLADO SOCIEDAD LIMITADA.
Ampliación de capital. Capital: 40.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 66.000,00 Euros. Datos registrales. T 1004, L 768, F 162, S
8, H AB 27351, I/A 2 2.01.20.
9154 - PROMOCIONES HUERTA Y FRANKLIN SOCIEDAD LIMITADA.
Ceses/Dimisiones. Liquidador: PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES SIMCABAL SOCIEDAD LIM. Adm. Unico: PROMOCIONES
Y CONSTRUCCIONES SIMCABAL SOCIEDAD LIM. Nombramientos. Liquidador: PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES
SIMCABAL SOCIEDAD LIM. Disolución. Voluntaria. Extinción. Datos registrales. T 977, L 741, F 4, S 8, H AB 25777, I/A 2
3.01.20.
9155 - CANTERO DE LETUR SOCIEDAD ANONIMA.
Reelecciones. Adm. Unico: CUERVO ARANGO LECINA PABLO. Datos registrales. T 748, L 512, F 61, S 8, H AB 236, I/A 13
2.01.20.
9156 - CAFE TOÑI LLOPART SOCIEDAD LIMITADA.
Ceses/Dimisiones. Liquidador: GALLEGO MORENO JUAN GABRIEL. Adm. Unico: GALLEGO MORENO JUAN GABRIEL.
Nombramientos. Liquidador: GALLEGO MORENO JUAN GABRIEL. Disolución. Voluntaria. Extinción. Datos registrales. T 661, L 425, F 121, S 8, H AB 8932, I/A 4 2.01.20.
cve: BORME-A-2020-7-02
Verificable en https www.boe.es
9153 - LOGISTICA SAN PASCUAL SOCIEDAD LIMITADA.
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: SANCHEZ MARTINEZ VICEDO. Cambio de domicilio social. C/ CORDOBA, 67 2º B 02006
ALBACETE. Datos registrales. T 951, L 715, F 101, S 8, H AB 24545, I/A 2 2.01.20.