Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 22/9/2020 - Empresarios
Text version What is this?Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.
Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Empresarios
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 184
Martes 22 de septiembre de 2020
Pág. 34093
SECCIÓN PRIMERA
Empresarios Actos inscritos ALBACETE
316852 - AUTOMOVILES DANI 2018 SOCIEDAD LIMITADA.
Fe de erratas: Por error se indico como la domicilio la población de La Roda, cuando en realidad el domicilio social es en la Población de ALBACETE. Datos registrales. T 1004, L 768, F 129, S 8, H AB 27340, I/A 1 20.02.19.
316853 - AUTOMOVILES DANI 2018 SOCIEDAD LIMITADA.
Declaración de unipersonalidad. Socio único: CARRION GARCIA LUCIA. Datos registrales. T 1004, L 768, F 132, S 8, H AB
27340, I/A 2 14.09.20.
316854 - HIJOS RESTAURANTE EL GALGO SOCIEDAD LIMITADA.
Ceses/Dimisiones. Liquidador M: SALMERON DEL PUEBLO REMEDIOS;LOPEZ SALMERON ANGEL. Adm. Mancom.: SALMERON
DEL PUEBLO REMEDIOS;LOPEZ SALMERON MARIA LUCIA;LOPEZ SALMERON NURIA;LOPEZ SALMERON ANGEL.
Nombramientos. Liquidador M: SALMERON DEL PUEBLO REMEDIOS;LOPEZ SALMERON ANGEL. Disolución. Voluntaria.
Extinción. Datos registrales. T 907, L 671, F 154, S 8, H AB 22086, I/A 2 10.09.20.
316855 - SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS HELLIN SOCIEDAD LIMITADA.
Cambio de domicilio social. C/ LIBERTAD, 123 02400 HELLIN. Datos registrales. T 997, L 761, F 2, S 8, H AB 19393, I/A 3
14.09.20.
316856 - GABINETE TECNICO DE SOFTWARE SOCIEDAD LIMITADA.
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: MARIN CORTES FRANCISCO JAVIER. Nombramientos. Adm. Solid.: MARIN CORTES
FRANCISCO JAVIER;CORREDOR BLAZQUEZ MARIA LLANOS. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración:
Administrador único a Administradores solidarios. Datos registrales. T 693, L 457, F 216, S 8, H AB 79, I/A 14 14.09.20.
316857 - EXPLOTACIONES AGRICOLAS Y GANADERAS LOS CAÑALIZOS SOCIEDAD LIMITADA.
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: GARIJO BUFORT JOAQUIN. Nombramientos. Adm. Unico: GARIJO GONZALEZ JOAQUIN.
Datos registrales. T 998, L 762, F 158, S 8, H AB 26440, I/A 4 14.09.20.
316858 - EXCLUSIVAS DEL BEBE SOCIEDAD ANONIMA LABORAL.
Reelecciones. Adm. Solid.: LOPEZ SIMARRO JOSE;MOYA CONTRERAS ANTONIO. Datos registrales. T 537, L 301, F 221, S 8, H
AB 7140, I/A 6 14.09.20.
316859 - EXCLUSIVAS DEL BEBE SOCIEDAD ANONIMA LABORAL.
Adaptación Ley 44/2015. Datos registrales. T 537, L 301, F 221, S 8, H AB 7140, I/A 7 14.09.20.
316861 - HERMANDAD FARMACEUTICA SOCIEDAD LIMITADA.
Ceses/Dimisiones. Liquidador: FELGUERAS BETETA MIGUEL. Adm. Unico: FELGUERAS BETETA OSCAR. Nombramientos.
Liquidador: FELGUERAS BETETA MIGUEL. Disolución. Voluntaria. Extinción. Datos registrales. T 976, L 740, F 139, S 8, H AB
25750, I/A 3 14.09.20.
316862 - MARVIMUSICA SOCIEDAD LIMITADA.
Nombramientos. Apoderado: VILLAESCUSA NAVAJAS JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 976, L 740, F 217, S 8, H AB 16408, I/A 6 14.09.20.
cve: BORME-A-2020-184-02
Verificable en https www.boe.es
316860 - TRANSPORTES JULIAN CONDE SOCIEDAD LIMITADA.
Constitución. Comienzo de operaciones: 9.09.20. Objeto social: el transporte de mercancías por carretera; el comercio al por mayor de cereales, simientes, plantas, abonos, sustancias fertilizantes, plaguicidas y alimentos para el ganado; el comercio al por menor de vehículos terrestres, lubricantes, accesorios, piezas de recambios y herramientas para los mismos. Domicilio: AVDA JOSE
HERNANDEZ DE LA ASUNCION, 3 4º 02640 ALMANSA. Capital: 90.000,00 Euros. Nombramientos. Adm. Unico: CONDE DURO
JULIAN. Datos registrales. T 1021, L 785, F 102, S 8, H AB 28309, I/A 1 14.09.20.