Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 24/3/2020 - Empresarios

Text version What is this?Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Empresarios

BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 58

Martes 24 de marzo de 2020

Pág. 13846

130012 - LUXURY PROPERTY INVEST ALBIR SL.
Constitución. Comienzo de operaciones: 11.02.20. Objeto social: Promoción, construcción, rehabilitación, mantenimiento y reforma de inmuebles y obras. Actividades inmobiliarias. Intermediación en el asesoramiento, compraventa, explotación y arrendamiento -no financierode todo tipo de inmuebles y maquinaria. Domicilio: C/ BERLIN 1 5 FINESTRAT. Capital: 3.000,00 Euros. Declaración de unipersonalidad. Socio único: KAPLIN NIKOLAY. Nombramientos. Adm. Unico: MESA ARTEM MACHADO. Datos registrales. T
4287 , F 78, S 8, H A 169387, I/A 1 16.03.20.
130013 - LAUK-MAGDALA SL.
Ampliación de capital. Capital: 80.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 83.000,00 Euros. Datos registrales. T 4016 , F 45, S 8, H A
153982, I/A 3 16.03.20.
130014 - CANTERAS DEL FACTOR SL.
Revocaciones. Apoderado: RUEDA MIRA REMEDIOS MARIA;GARCIA RUIZ JUAN PEDRO. Datos registrales. T 4135 , F 154, S 8, H A 158983, I/A 10 16.03.20.
130015 - SENTITS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SL.
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: VALDES BOLUFER PAULA. Reelecciones. Adm. Solid.: RUIZ CARBONELL MARIA DEL
PILAR;NAVARRO AMAT SILVIA. Datos registrales. T 3712 , F 26, S 8, H A 136312, I/A 3 16.03.20.
130016 - LOVECITA LOVERS SL.
Constitución. Comienzo de operaciones: 17.09.19. Objeto social: La actividad dirección, control y prestación de servicios de apoyo a la gestión de las actividades desarrolladas por sociedades participadas, tales como los servicios de carácter administrativo -como la contabilidad, gestión de cobros, organización de recursos, etc.-, los relacionados con las activi. Domicilio: AVDA DEL PLA 126 CENTRO COMERCIAL ARENA OFICINA JAVEA. Capital: 714.567,88 Euros. Declaración de unipersonalidad. Socio único:
MERTENS STEPHANIE. Nombramientos. Adm. Unico: MERTENS STEPHANIE. Datos registrales. T 4287 , F 82, S 8, H A 169389, I/A 1 16.03.20.
130017 - CELIBEN SOCIEDAD LIMITADA.
Nombramientos. Apoderado: DOMINGO GARCIN ENRIQUE MANUEL. Datos registrales. T 1447 , F 55, S 8, H A 13741, I/A 3
16.03.20.
130018 - LAURA MERTENS SL.
Constitución. Comienzo de operaciones: 17.09.19. Objeto social: La actividad dirección, control y prestación de servicios de apoyo a la gestión de las actividades desarrolladas por sociedades participadas, tales como los servicios de carácter administrativo -como la contabilidad, gestión de cobros, organización de recursos, etc.-, los relacionados con las activi. Domicilio: AVDA DEL PLA, 126 CENTRO COMERCIAL ARENAL OFICI JAVEA. Capital: 714.567,88 Euros. Declaración de unipersonalidad. Socio único:
MERTENS LAURA. Nombramientos. Adm. Unico: MERTENS LAURA. Datos registrales. T 4288 , F 82, S 8, H A 169390, I/A 1
16.03.20.
130019 - CIRILO IMPORTACIONES SL.
Modificaciones estatutarias. Artículo 13. Duración del cargo de administrador y retribución del mismo. Datos registrales. T 2939 , F
56, S 8, H A 92637, I/A 4 16.03.20.

130021 - ALLEGRA TEXTIL SL.
Constitución. Comienzo de operaciones: 27.02.20. Objeto social: La intermediación y comercio al por mayor de toda clase de textiles así como la fabricación de productos textiles. Domicilio: AVDA DE BENEIXAMA 2 D - POLIGONO INDUSTRIAL ELS DO BIAR.
Capital: 10.000,00 Euros. Nombramientos. Adm. Unico: MARTINEZ ALBERO ANTONIO. Datos registrales. T 4288 , F 87, S 8, H A
169392, I/A 1 16.03.20.
130022 - JOYERIA GOMEZ SA.
Cancelaciones de oficio de nombramientos. Consejero: HERNANDEZ MARIN MARIA ISABEL;HERNANDEZ MARIN MARIA
TERESA;HERNANDEZ VERDU FRANCISCO;HERNANDEZ GOMEZ FRANCISCO;HERNANDEZ GOMEZ MARIA ASUNCION.
Con.Delegado: HERNANDEZ MARIN MARIA ISABEL. Secretario: HERNANDEZ VERDU FRANCISCO. Consejero: VERDU
HERNANDEZ MATILDE. Presidente: VERDU HERNANDEZ MATILDE. Nombramientos. Consejero: VERDU HERNANDEZ
MATILDE;HERNANDEZ VERDU FRANCISCO;HERNANDEZ MARIN MARIA ISABEL;HERNANDEZ MARIN MARIA
TERESA;HERNANDEZ GOMEZ FRANCISCO;HERNANDEZ GOMEZ MARIA ASUNCION. Presidente: HERNANDEZ VERDU
FRANCISCO. Secretario: VERDU HERNANDEZ MATILDE. Con.Delegado: HERNANDEZ MARIN MARIA TERESA. Datos registrales. T 1368 , F 9, S 8, H A 9760, I/A 11 16.03.20.

cve: BORME-A-2020-58-03
Verificable en https www.boe.es
130020 - AGROFUTURA LEVANTE SL.
Constitución. Comienzo de operaciones: 5.03.20. Objeto social: Agricultura. Domicilio: CMNO VIEJO DE CALLOSA 51 ORIHUELA.
Capital: 3.000,00 Euros. Nombramientos. Adm. Unico: TORRES GALINDO ANTONIO. Datos registrales. T 4287 , F 87, S 8, H A
169391, I/A 1 16.03.20.

About this edition

Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 24/3/2020 - Empresarios

TitleBoletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Empresarios

CountrySpain

Date24/03/2020

Page count160

Edition count3270

First edition03/01/2011

Last issue03/05/2024

Download this edition

Other editions

<<<Marzo 2020>>>
DLMMJVS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031