Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 19/3/2020 - Empresarios

Text version What is this?Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Empresarios

BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 55

Jueves 19 de marzo de 2020

Pág. 13223

124360 - PANELES ACUSTICOS ECO CERO SL.
Modificaciones estatutarias. Remuneración del administrador. Cambio de domicilio social. C/ BRONCE 8-B - AREA
INDUSTRIAL TORREGROSES SAN VICENTE DEL RASPEIG. Datos registrales. T 4016 , F 185, S 8, H A 154052, I/A 5 11.03.20.
124361 - SAGASOLAR SL.
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: MORALES QUESADA MIGUEL. Ceses/Dimisiones. Adm. Unico:
TOMAS GARAÑANA JESUS. Nombramientos. Adm. Unico: MORALES QUESADA MIGUEL. Ampliación de capital. Capital:
140.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 143.200,00 Euros. Cambio de domicilio social. URB BONALBA 12 BUSOT. Datos registrales. T 3222 , F 41, S 8, H A 108578, I/A 3 11.03.20.
124362 - SERA PRODOS SL.
Cambio de domicilio social. C/ COCENTAINA 8 CASTALLA. Datos registrales. T 3885 , F 132, S 8, H A 146509, I/A 2 11.03.20.
124363 - GHOLMA QIVA SL.
Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ SELVA ALBERTO. Datos registrales. T 3649 , F 171, S 8, H A 131185, I/A 7 11.03.20.
124364 - TEXTIL ESTAMBUL SL.
Constitución. Comienzo de operaciones: 24.01.20. Objeto social: Comercio al por mayor y menor de artículos textiles y complementos para vestir así como artículos de regalos y los típicos de los bazares. Domicilio: POLIG DEL BOCH 6 CREVILLENT.
Capital: 3.000,00 Euros. Nombramientos. Adm. Solid.: AJBARI AZZEEDDINE;ETTAMIMI LEKBIR. Datos registrales. T 4285 , F
201, S 8, H A 169333, I/A 1 11.03.20.
124365 - DUBIO STATUM SL.
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: DELGADO FERRER MANUEL. Nombramientos. Adm. Unico: BONO ROBERTO. Ampliacion del objeto social. Intermediación en servicios administrativos y de gestión. Cambio de domicilio social. C/ PINTOR APARICIO 21
BAJO ALICANTE. Datos registrales. T 4155 , F 2, S 8, H A 161781, I/A 2 11.03.20.
124366 - TIC CERTIFICACION IBERICA SL.
Constitución. Comienzo de operaciones: 6.02.20. Objeto social: Certificación de sistemas de gestión empresarial, Auditorías de sistemas de gestión empresarial y formación. Domicilio: AVDA PINTOR PEREZ GIL 13 12 ALICANTE. Capital: 3.000,00 Euros.
Declaración de unipersonalidad. Socio único: MARTI SANTAMARIA PATRICIA REBECA. Nombramientos. Adm. Unico:
TORREGROSA RODRIGUEZ PEDRO LUIS. Datos registrales. T 4286 , F 202, S 8, H A 169332, I/A 1 11.03.20.
124367 - PALETS LA ANTENA SL.
Constitución. Comienzo de operaciones: 7.02.20. Objeto social: Fabricación, transformación, manipulación, comerico al por mayor y al por menor, importación y exportación de toda clase de madera y demás artículos de carpintería y ebanistería.- Carpintería y ebanistería en general. Domicilio: AVDA DEL ZODIACO S/N - NAVE 5, POLIGONO INDUSTRIAL ALICANTE. Capital: 3.000,00
Euros. Nombramientos. Adm. Unico: DANTAS PEIXOTO SERGIO. Datos registrales. T 4285 , F 205, S 8, H A 169335, I/A 1
11.03.20.
124368 - RAHIER PROPIEDAD SL.
Cambio de domicilio social. C/ COCENTAINA 8 CASTALLA. Datos registrales. T 4046 , F 223, S 8, H A 155790, I/A 2 11.03.20.

124370 - PROMOCIONES ESMARGA SL.
Pérdida del caracter de unipersonalidad. Reducción de capital. Importe reducción: 0,25 Euros. Resultante Suscrito: 68.098,00
Euros. Ampliación de capital. Capital: 170.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 238.098,00 Euros. Datos registrales. T 2371 , F 218, S 8, H A 60985, I/A 5 11.03.20.
124371 - R. R. PALADIUM BENIDORM SL.
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: GOMEZ ORTEGA OSCAR. Nombramientos. Adm. Solid.: GOMEZ ORTEGA OSCAR;GOMEZ
ORTEGA LAURA. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios.
Cambio de domicilio social. AVDA DEL MEDITERRANEO 43 - LOCALES 9, 10 Y 11 BENIDORM. Datos registrales. T 2829 , F
192, S 8, H A 86375, I/A 5 11.03.20.
124372 - BOMBON BOSS SL.
Nombramientos. Apoderado: SEMPERE PEDRADA MANUEL. Datos registrales. T 4271 , F 220, S 8, H A 71365, I/A 9 11.03.20.

cve: BORME-A-2020-55-03
Verificable en https www.boe.es
124369 - ELEGITY SL.
Ampliacion del objeto social. 3. Salón de belleza. 4. Servicio de peluquería unisex. 5. Servicios deportivos. 6. Servicios de hostelería, cafetería, restaurante y quiosco. 7. Servicio de organización de congresos y asambleas. 8. Supermercado autoservicio. 9.
Comercio al por mayor y por menor de productos alimenticios, bebidas, t. Datos registrales. T 4129 , F 155, S 8, H A 160413, I/A 2
11.03.20.

About this edition

Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 19/3/2020 - Empresarios

TitleBoletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Empresarios

CountrySpain

Date19/03/2020

Page count274

Edition count3272

First edition03/01/2011

Last issue07/05/2024

Download this edition

Other editions

<<<Marzo 2020>>>
DLMMJVS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031