Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 5/11/2019 - Empresarios
Text version What is this?*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.
Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Empresarios
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 212
Martes 5 de noviembre de 2019
Pág. 48458
SECCIÓN PRIMERA
Empresarios Actos inscritos ALBACETE
455476 - TAPIZADOS PEYVAN SOCIEDAD LIMITADA.
Nombramientos. Apoderado: RIVERA QUIROZ MARCELA. Datos registrales. T 986, L 750, F 146, S 8, H AB 11166, I/A 7
25.10.19.
455477 - RESTYLE FURNITURE SOCIEDAD LIMITADA.
Nombramientos. Apoderado: RIVERA QUIROZ MARCELA. Datos registrales. T 927, L 691, F 93, S 8, H AB 23083, I/A 4
25.10.19.
455478 - EVERCODE SOCIEDAD LIMITADA.
Ceses/Dimisiones. Liquidador: GONZALEZ MEDRANO MIGUEL ANGEL. Adm. Unico: GONZALEZ MEDRANO MIGUEL ANGEL.
Nombramientos. Liquidador: GONZALEZ MEDRANO MIGUEL ANGEL. Disolución. Voluntaria. Extinción. Datos registrales. T
921, L 685, F 62, S 8, H AB 22841, I/A 3 25.10.19.
455479 - RENOVALIA RTS INVEST SOCIEDAD LIMITADA.
Ceses/Dimisiones. Liquidador M: OLEA AVILES JOSE MANUEL;GIL ACACIO MARIA DEL PILAR. Adm. Mancom.: GIL ACACIO
MARIA DEL PILAR;OLEA AVILES JOSE MANUEL. Revocaciones. Apo.Sol.: GIL ACACIO MARIA DEL PILAR. Nombramientos.
Liquidador M: OLEA AVILES JOSE MANUEL;GIL ACACIO MARIA DEL PILAR. Disolución. Voluntaria. Extinción. Datos registrales. T 991, L 755, F 210, S 8, H AB 20508, I/A 14 24.10.19.
455480 - GRANELES EL CUADRO SOCIEDAD LIMITADA.
Ceses/Dimisiones. LiquiSoli: ALBIAR MOYA ENRIQUE;MARTINEZ MARTINEZ PABLO. Adm. Solid.: ALBIAR MOYA
ENRIQUE;MARTINEZ MARTINEZ PABLO. Nombramientos. LiquiSoli: ALBIAR MOYA ENRIQUE;MARTINEZ MARTINEZ PABLO.
Disolución. Voluntaria. Extinción. Datos registrales. T 1005, L 769, F 27, S 8, H AB 27382, I/A 2 24.10.19.
455481 - COIDESALBA SOCIEDAD LIMITADA.
Declaración de unipersonalidad. Socio único: GONZALEZ MARTINEZ CARLOS JAVIER. Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.:
GONZALEZ MARTINEZ CARLOS JAVIER;PIQUERAS SAEZ ANGELINA ISABEL. Nombramientos. Adm. Unico: GONZALEZ
MARTINEZ CARLOS JAVIER. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único. Cambio de domicilio social. C/ DOCTOR COLLADO PIÑA, 71 Bajo 02003 ALBACETE. Datos registrales. T
985, L 749, F 54, S 8, H AB 26260, I/A 2 28.10.19.
455482 - SERTECALBA SOCIEDAD LIMITADA.
Nombramientos. Apoderado: SOTOS LOPEZ JUAN LUIS. Datos registrales. T 988, L 752, F 126, S 8, H AB 26455, I/A 2
27.10.19.
455484 - JIMOSOLAR SOCIEDAD LIMITADA.
Constitución. Comienzo de operaciones: 18.10.19. Objeto social: A.- El asesoramiento, desarrollo, construcción, explotación y/o titularidad de activos de generación de energía eléctrica de fuentes renovables, y especialmente energía solar fotovoltaica y energía eólica, previo cumplimiento de los trámites y requisitos administrativos especiales que pudieran veni. Domicilio: PRAJE LOMA DEL
GALLEGO, 58 HELLIN. Capital: 3.200,00 Euros. Nombramientos. Adm. Solid.: MORENO JIMENEZ FRANCISCO
JAVIER;MORENO LOPEZ FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 1011, L 775, F 198, S 8, H AB 27806, I/A 1 28.10.19.
455485 - GASTROBAREO HOSTELERIA SOCIEDAD LIMITADA LABORAL.
Nombramientos. Apoderado: MAYORAL GONZALEZ PEDRO ANGEL. Datos registrales. T 1011, L 775, F 44, S 8, H AB 27766, I/A
2 28.10.19.
cve: BORME-A-2019-212-02
455483 - MIGUEL SOCIEDAD LIMITADA.
Reducción de capital. Importe reducción: 500.333,26 Euros. Resultante Suscrito: 2.144.120,00 Euros. Datos registrales. T 789, L
553, F 5, S 8, H AB 2298, I/A 7 28.10.19.