Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 11/9/2018 - Empresarios

Text version What is this?Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Empresarios

BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 175

Martes 11 de septiembre de 2018

Pág. 39820

VELA BARCA JAVIER;GARCIA ALVAREZ MANUEL ANGEL;ROMAN HERNANDEZ JUAN VICENTE. Apo.Sol.: MUNT BOSCH JOSE.
Apo.Man.Soli: MUNT BOSCH JOSE. Apo.Sol.: REYES GARCIA CARLOS. Apo.Man.Soli: REYES GARCIA CARLOS;HERNANDEZ
BLANCO LUIS;HERNANDEZ BLANCO LUIS;HERNANDEZ BLANCO LUIS;HERNANDEZ BLANCO LUIS. Datos registrales. T 4149 , F 152, S 8, H A 95157, I/A 107 30.08.18.
370258 - ACTIVA TU ACCESO SL.
Ampliación de capital. Capital: 18.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 21.000,00 Euros. Cambio de denominación social.
ONDYTEC 2018 SL. Datos registrales. T 4146 , F 70, S 8, H A 161272, I/A 3 3.09.18.
370259 - ALQUILER VACACIONAL ALICANTE SL.
Nombramientos. Apoderado: DEL REY PEREZ FELIPE. Datos registrales. T 4061 , F 130, S 8, H A 156535, I/A 2 3.09.18.
370260 - NOVELDA STONE SL.
Reapertura hoja registral. Datos registrales. T 2424 , F 59, S 8, H A 63938, I/A 1 1 3.09.18.
370261 - MARJON & NAVALMORAL MEDIACION SL.
Constitución. Comienzo de operaciones: 29.08.18. Objeto social: La intermediación en la contratación de seguros en concepto de agencia vinculada, siendo ésta la actividad principal de la Sociedad; así como la gestión y asesoramiento de todo tipo de gestiones ante las distintas administraciones a particulares y empresas, laboral y contable. La mediación y asesora. Domicilio: C/ HERMANAS
OLIVER 98 BAJO TEULADA. Capital: 3.010,00 Euros. Nombramientos. Adm. Unico: NAVALMORAL MAS SANDRA. Apoderado:
NAVALMORAL DEL OLMO JOSE LUIS. Datos registrales. T 4152 , F 63, S 8, H A 161594, I/A 1 3.09.18.
370262 - FRANPADIMA SL.
Constitución. Comienzo de operaciones: 29.08.18. Objeto social: La explotación de negocios de cafetería, cervecería, restaurantes, pubs y discoteca. Domicilio: AVDA CONDES DE SOTO AMENO 53 BAJO ALICANTE. Capital: 4.000,00 Euros. Declaración de unipersonalidad. Socio único: PADILLA SOLBES MIGUEL. Nombramientos. Adm. Unico: PADILLA SOLBES MIGUEL. Datos registrales. T 4152 , F 68, S 8, H A 161596, I/A 1 3.09.18.
370263 - INMO CENTRO SOCIEDAD ANONIMA.
Reelecciones. Adm. Unico: ALBALADEJO ESCUDERO DOMINGO. Datos registrales. T 1270 , F 59, S 8, H A 5094, I/A 9
3.09.18.
370264 - MED-HOTELS INVEST SL.
Constitución. Comienzo de operaciones: 2.07.18. Objeto social: La promoción, construcción -por cuenta propia o de terceros-, compra, venta,y arrendamiento de toda clase de edificaciones. La compra, urbanización, parcelación y venta de toda clase de fincas rústicas o urbanas. La explotación de toda clase de negocios de restauración, bares, cafeterías, confitería. Domicilio: AVDA ANGEL
GARCIA ROGEL 2 - URBANIZACION VILLASOL TORREVIEJA. Capital: 25.000,00 Euros. Nombramientos. Adm. Unico: CHAIB
AMAR NASSIM. Apoderado: TORRES SIMON ROSA ANA. Datos registrales. T 4152 , F 72, S 8, H A 161598, I/A 1 3.09.18.
370265 - INVERPEYMASA SL.
Revocaciones. Apoderado: SAEZ NAVARRETE PEDRO. Datos registrales. T 3837 , F 100, S 8, H A 143685, I/A 7 3.09.18.
370266 - BALCONES DEL VINALOPO SL.
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: FUSTER SELVA FRANCISCO. Ceses/Dimisiones. Adm. Unico:
CANOVAS CANO ANTONIO. Nombramientos. Adm. Unico: FUSTER SELVA FRANCISCO. Cambio de domicilio social. C/
HERMANOS GONZALVEZ SELVA 2 ELCHE. Datos registrales. T 3648 , F 124, S 8, H A 132566, I/A 2 3.09.18.

370268 - JUAN Y LOLI AUTOESCUELA SL.
Constitución. Comienzo de operaciones: 30.08.18. Objeto social: Actividades de las autoescuelas de conducción y pilotaje. Domicilio:
C/ UNION MUSICAL TORREVEJENSE 37 TORREVIEJA. Capital: 3.000,00 Euros. Nombramientos. Adm. Mancom.: FERNANDEZ
FERRI JUAN JESUS;PEREZ PENALVA MARIA DOLORES. Datos registrales. T 4151 , F 77, S 8, H A 161595, I/A 1 3.09.18.
370269 - GRUPO LEON GRAFICA CREATIVA SL.
Constitución. Comienzo de operaciones: 30.08.18. Objeto social: 1. Construcción, instalaciones y mantenimiento. 2. Comercio al por mayor y al por menor. Distribución comercial. Importación y exportación. 3. Actividades inmobiliarias. 4. Industrias manufactureras y textiles. 5. Turismo, hostelería y restauración. 6. Prestación de servicios. Actividades de gestión. Domicilio: C/ SANTA TERESA 21
ALTEA. Capital: 3.000,00 Euros. Declaración de unipersonalidad. Socio único: JIMENEZ LEON FRANCISCO. Nombramientos.
Adm. Unico: JIMENEZ LEON FRANCISCO. Datos registrales. T 4151 , F 83, S 8, H A 161599, I/A 1 3.09.18.

cve: BORME-A-2018-175-03

370267 - MUNDICAR SA.
Nombramientos. Apo.Manc.: MIRA SANCHEZ JOSE ANTONIO;CALATAYUD RIGAU VIRGINIA;GONSALBEZ ALARCON JOSE
JAVIER Datos registrales. T 3726 , F 199, S 8, H A 10442, I/A 44 3.09.18.

About this edition

Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 11/9/2018 - Empresarios

TitleBoletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Empresarios

CountrySpain

Date11/09/2018

Page count202

Edition count3270

First edition03/01/2011

Last issue03/05/2024

Download this edition

Other editions

<<<Septiembre 2018>>>
DLMMJVS
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30