Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 28/11/2019 - Empresarios

Versione di testo Cosa è?Dateas è un sito indipendente non affiliato a entità governative. La fonte dei documenti PDF che pubblichiamo qui è l'entità governativa indicata in ciascuno di essi. Le versioni in testo sono trascrizioni che realizziamo per facilitare l'accesso e la ricerca di informazioni, ma possono contenere errori o non essere complete.

Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Empresarios

BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 229

Jueves 28 de noviembre de 2019

Pág. 52333

Compra y venta de vehículos. Alquiler y venta de inmuebles. Domicilio: AVDA SATURNO 11 ALICANTE. Capital: 3.000,00 Euros.
Declaración de unipersonalidad. Socio único: CERVERA GARCIA FRANCISCO. Nombramientos. Adm. Unico: CERVERA
GARCIA FRANCISCO. Datos registrales. T 4256 , F 155, S 8, H A 167548, I/A 1 20.11.19.
491607 - CALP SCARPE SL.
Nombramientos. Apoderado: BERBEGAL IBAÑEZ RAUL. Datos registrales. T 4023 , F 219, S 8, H A 154407, I/A 3 20.11.19.
491608 - ARESI GESTION RESIDENCIAL SL.
Nombramientos. Apoderado: SANZ DIEZ BEATRIZ. Datos registrales. T 4175 , F 184, S 8, H A 153703, I/A 22 20.11.19.
491609 - TIMAYLA SL.
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: MARTINEZ SAN NICOLAS ISAIAS. Ceses/Dimisiones. Adm.
Unico: YESTE TORRES LAURA. Nombramientos. Adm. Unico: MARTINEZ SAN NICOLAS ISAIAS. Datos registrales. T 4197 , F
223, S 8, H A 164257, I/A 2 20.11.19.
491610 - AFINEM ADMINISTRACIO DE FINQUES SL.
Nombramientos. Apoderado: SANZ DIEZ BEATRIZ. Datos registrales. T 4104 , F 83, S 8, H A 112752, I/A 21 20.11.19.
491611 - ELCHE ADMINISTRACION DE FINCAS SL.
Nombramientos. Apoderado: SANZ DIEZ BEATRIZ. Datos registrales. T 4104 , F 89, S 8, H A 116466, I/A 18 20.11.19.
491612 - ADMINISTRACION URBANA Y RURAL CHORRO SL.
Nombramientos. Apoderado: SANZ DIEZ BEATRIZ. Datos registrales. T 4210 , F 195, S 8, H A 36092, I/A 25 20.11.19.
491613 - CALZADOS ORTUÑO E HIJOS SL.
Cambio de domicilio social. C/ VALVERDE DEL CAMINO 1 - POLIGONO INDUSTRIAL DE ELCHE. Datos registrales. T 3908 , F
78, S 8, H A 147858, I/A 3 20.11.19.
491614 - NOU MIL.LENNI MOBILIARIO SL.
Declaración de unipersonalidad. Socio único: SANCHEZ SERRANO JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 2364 , F 138, S 8, H A
60634, I/A 4 20.11.19.
491615 - STEIN WORLD TRADERS SL.
Nombramientos. Apoderado: CANO PEREZ REBECA. Datos registrales. T 4253 , F 22, S 8, H A 167363, I/A 2 20.11.19.
491616 - GRUPO EMPRESARIAL MIGUEL ANGEL AGUILAR SL.
Constitución. Comienzo de operaciones: 14.11.19. Objeto social: Arrendamiento de toda clase de inmbuebles. Actividades de las sedes centrales. Domicilio: C/ HERMANOS ALVAREZ QUINTERO 3 2º RAFAL. Capital: 3.000,00 Euros. Declaración de unipersonalidad. Socio único: AGUILAR HERRERO MIGUEL ANGEL. Nombramientos. Adm. Unico: AGUILAR HERRERO
MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 4256 , F 163, S 8, H A 167550, I/A 1 20.11.19.

491618 - FAMILIA PIÑANA SA.
Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Man: PIÑANA FUSTER MARIA JOSE;PIÑANA FUSTER CARMEN MARIA;PIÑANA FUSTER
JORGE;PIÑANA FUSTER MARIA ROSARIO. Nombramientos. Cons.Del.Man: PIÑANA FUSTER MARIA JOSE;PIÑANA FUSTER
JORGE;PIÑANA FUSTER MARIA ROSARIO;PIÑANA FUSTER CARMEN MARIA. Reelecciones. Consejero: PIÑANA FUSTER
MARIA JOSE;PIÑANA FUSTER JORGE;PIÑANA FUSTER MARIA ROSARIO;PIÑANA FUSTER CARMEN MARIA. Presidente:
PIÑANA FUSTER MARIA JOSE. Vicepresid.: PIÑANA FUSTER JORGE. Secretario: PIÑANA FUSTER CARMEN MARIA. Datos registrales. T 1496 , F 26, S 8, H A 16058, I/A 7 20.11.19.
491619 - PROMOCIONES JILOCASOL SL.
Ceses/Dimisiones. LiquiSoli: GAMON YUSTE ALBERTO;GIMENEZ MORA FRANCISCO;GAMON YUSTE FRANCISCO JAVIER.
Adm. Solid.: GIMENEZ MORA FRANCISCO;GAMON YUSTE FRANCISCO JAVIER;GAMON YUSTE ALBERTO. Nombramientos.
LiquiSoli: GIMENEZ MORA FRANCISCO;GAMON YUSTE FRANCISCO JAVIER;GAMON YUSTE ALBERTO. Disolución. Voluntaria.
Extinción. Datos registrales. T 2156 , F 139, S 8, H A 49752, I/A 4 20.11.19.
491620 - CONFRAMI REFORMAS SL.
Constitución. Comienzo de operaciones: 8.11.19. Objeto social: Promoción inmobiliaria. Construcción de todo tipo de edificios.
Promoción inmobiliaria. Arrendamiento de todo tipo de bienes rústicos y urbanos. Domicilio: C/ LA BODEGA 3 1º G - SEGUNDA FASE
RAFAL. Capital: 3.000,00 Euros. Declaración de unipersonalidad. Socio único: HERNANDEZ ARQUES FRANCISCO MIGUEL.

cve: BORME-A-2019-229-03
Verificable en https www.boe.es
491617 - EDIFICIOS COSTA SOCIEDAD LIMITADA EN LIQUIDACION.
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: COSTA ABAD JACINTO;COSTA ABAD JOSE. Nombramientos. Liquidador: COSTA ABAD
JACINTO. Disolución. Otras Causas. Datos registrales. T 1226 , F 14, S 8, H A 3148, I/A 3 20.11.19.

Riguardo a questa edizione

Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 28/11/2019 - Empresarios

TitoloBoletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Empresarios

PaeseSpagna

Data28/11/2019

Conteggio pagine229

Numero di edizioni3276

Prima edizione03/01/2011

Ultima edizione06/06/2024

Scarica questa edizione

Altre edizioni

<<<Noviembre 2019>>>
DLMMJVS
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930