Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 9/8/2011 - Empresarios
Versione di testo Cosa è?Dateas è un sito indipendente non affiliato a entità governative. La fonte dei documenti PDF che pubblichiamo qui è l'entità governativa indicata in ciascuno di essi. Le versioni in testo sono trascrizioni che realizziamo per facilitare l'accesso e la ricerca di informazioni, ma possono contenere errori o non essere complete.
Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Empresarios
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 151
Martes 9 de agosto de 2011
Pág. 40498
SECCIÓN PRIMERA
Empresarios Actos inscritos ALICANTE
330951 - FELICI E CONTENTI SL.
Constitución. Comienzo de operaciones: 21.03.11. Objeto social: la elaboración y venta al por menor de productos de heladería y pasteleríaartesanal. Domicilio: C/ MEDICO PASCUAL PEREZ 29 BAJO ALICANTE. Capital: 3.100,00 Euros. Nombramientos.
Adm. Unico: CASINI FRANCO. Datos registrales. T 3543 , F 113, S 8, H A 126415, I/A 1 25.07.11.
330952 - FARO ALQUILERES SA.
Reelecciones. Adm. Unico: SARANOVA ZOZAYA ROSA MARIA. Datos registrales. T 1566 , F 58, S 8, H A 19740, I/A 10
28.07.11.
330953 - PROYECTO ARKITUA SL.
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: ANTON ANTON JOSE JAIME;GODOY SERRANO MANUEL. Nombramientos. Adm. Mancom.:
DE LA COBA LOPEZ PASTOR MARIA ANTONIA. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administración:
Administradores mancomunados a Administrador único. Cambio de domicilio social. C/ ANTONIO CAMPOS JAVALOYES 5 BAJO
ELCHE. Datos registrales. T 3296 , F 149, S 8, H A 112768, I/A 2 28.07.11.
330954 - REGISTRADORAS Y SERVICIO TECNICO SL.
Cambio de domicilio social. C/ BENIFATO 1 - LOCAL 3 VILLAJOYOSA. Datos registrales. T 1677 , F 159, S 8, H A 25525, I/A 5
28.07.11.
330955 - BENILUX TERRA SL.
Ceses/Dimisiones. Liquidador: MANUYLOVA OLGA. Extinción. Datos registrales. T 3084 , F 140, S 8, H A 100786, I/A 3
28.07.11.
330956 - MARYOLI 2011 SL.
Constitución. Comienzo de operaciones: 23.06.11. Objeto social: a - La actividad propia de inmobiliaria y administración de fincas. El asesoramiento de actividades, tanto asesoramiento contable, fiscal, laboral, tal como actividades de franquicia, consultoría financiera y de asesoramiento. b - La llevanza de contabilidad, así como estudio y consejo de situacione. Domicilio: AVDA SANTANDER 25 CENTRO COMERCIAL GARDEN, LOCAL ALICANTE. Capital: 3.005,00 Euros. Declaración de unipersonalidad. Socio único:
CASTELLO AGULLO MARIA YOLANDA. Nombramientos. Adm. Unico: CASTELLO AGULLO MARIA YOLANDA. Datos registrales. T 3543 , F 192, S 8, H A 126455, I/A 1 28.07.11.
330957 - COMERCIAL ELECTRICA DIANENSE SA.
Reelecciones. Adm. Unico: ALBERT TORMO JUAN. Datos registrales. T 1877 , F 65, S 8, H A 13765, I/A 14 28.07.11.
330959 - RECTIFICADOS SAN VICENTE SAL.
Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: MARIN MARTINEZ JUAN. Nombramientos. Con.Delegado: MARIN MARTINEZ JUAN.
Reelecciones. Secretario: HERNANDEZ FUSTER ISIDRO. Vicesecret.: FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE. Vicepresid.: GIL GARCIA
JUAN JOSE. Consejero: GIL GARCIA JUAN JOSE;HERNANDEZ FUSTER ISIDRO;FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE;MARIN
MARTINEZ JUAN. Presidente: MARIN MARTINEZ JUAN. Datos registrales. T 1644 , F 22, S 8, H A 23694, I/A 6 28.07.11.
330960 - GOURMET MEALS SL.
Ampliación de capital. Capital: 1.014.900,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.758.650,00 Euros. Datos registrales. T 3222 , F 198, S
8, H A 108652, I/A 7 28.07.11.
330961 - AQUAGEST LEVANTE SA.
Revocaciones. Apoderado: BENITO LOPEZ MIGUEL ANGEL. Nombramientos. Apoderado: BENITO LOPEZ MIGUEL ANGEL.
Datos registrales. T 3327 , F 73, S 8, H A 44577, I/A 121 28.07.11.
cve: BORME-A-2011-151-03
330958 - TRANSPORTES JOSE BERNAL SERRANO SA EN LIQUIDACION.
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: GALLEGO BERMUDEZ FERNANDO;HERAS ROMANOS ISAAC. Nombramientos. Liquidador:
RICO GIRONA JUAN. Disolución. Voluntaria. Datos registrales. T 1439 , F 31, S 8, H A 13376, I/A 8 28.07.11.