Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 2/6/2011 - Empresarios
Versione di testo Cosa è?Dateas è un sito indipendente non affiliato a entità governative. La fonte dei documenti PDF che pubblichiamo qui è l'entità governativa indicata in ciascuno di essi. Le versioni in testo sono trascrizioni che realizziamo per facilitare l'accesso e la ricerca di informazioni, ma possono contenere errori o non essere complete.
Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Empresarios
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 105
Jueves 2 de junio de 2011
Pág. 28074
SECCIÓN PRIMERA
Empresarios Actos inscritos ALBACETE
234980 - ACHACALES SOCIEDAD LIMITADA.
Cambio de domicilio social. PSAJE DE GABRIEL LODARES 4 BAJO ALBACETE. Datos registrales. T 788, L 552, F 8, S 8, H AB
14150, I/A 3 24.05.11.
234981 - HAYA PROIN SOCIEDAD LIMITADA.
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: HAYA VALERO FRANCISCO;HAYA GONZALEZ FRANCISCO. Nombramientos. Adm. Unico:
NOTARIO GARCIA ANTONIO. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único. Cambio de domicilio social. C/ BALSA 56 GINETA LA. Datos registrales. T 797, L 561, F 29, S 8, H AB
14654, I/A 6 24.05.11.
234982 - GUGONSAN SOCIEDAD LIMITADA.
Declaración de unipersonalidad. Socio único: GONZALEZ MARTINEZ ANTONIO. Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: SANCHEZ
SANCHEZ JOSE LUIS. Nombramientos. Adm. Unico: GONZALEZ MARTINEZ ANTONIO. Datos registrales. T 820, L 584, F 54, S
8, H AB 15961, I/A 3 24.05.11.
234983 - GEOTECNIA Y CIMENTACIONES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA.
Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 144.443,00 Euros. Datos registrales. T 904, L 668, F 164, S 8, H AB 14115, I/A 5 24.05.11.
234984 - BOX CAPITAL ESPAÑA SOCIEDAD LIMITADA.
Cambio de domicilio social. POLIG INDUSTRIAL CAMPOLLANO - CALLE D, NUMERO 8 ALBACETE. Datos registrales. T 895, L 659, F 4, S 8, H AB 21323, I/A 7 24.05.11.
234985 - FINCAS Y SUELOS RUSTICOS SOCIEDAD LIMITADA.
Cambio de domicilio social. PSAJE FIRMAS 13 1 IZ ALBACETE. Datos registrales. T 907, L 671, F 58, S 8, H AB 22062, I/A 2
24.05.11.
234986 - APROVECHAMIENTOS ENERGETICOS BASTET SOCIEDAD LIMITADA.
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: VILLAR MOYA MARIA JOSE. Ceses/Dimisiones. Adm. Unico:
RAMIREZ RODRIGUEZ ISIDORO. Nombramientos. Adm. Unico: VILLAR MOYA MARIA JOSE. Cambio de domicilio social.
CTRA DE LEZUZA 6-D BONILLO EL. Datos registrales. T 907, L 671, F 61, S 8, H AB 22063, I/A 2 24.05.11.
234987 - CERROCUADRADO AGRICOLA SOCIEDAD LIMITADA.
Nombramientos. Apoderado: SANZ LOPEZ MARIA MERCEDES. Datos registrales. T 758, L 522, F 139, S 8, H AB 7637, I/A 4
24.05.11.
234989 - MELITAFE SOCIEDAD LIMITADA.
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: RUIZ BUENO FRANCISCO. Nombramientos. Apoderado: RUIZ BUENO FRANCISCO. Adm.
Unico: RUIZ LARA ANTONIO MONICO. Datos registrales. T 635, L 399, F 186, S 8, H AB 946, I/A 4 24.05.11.
234990 - MELITAFE SOCIEDAD LIMITADA.
Nombramientos. Apoderado: RUIZ BUENO FRANCISCO. Datos registrales. T 635, L 399, F 187, S 8, H AB 946, I/A 5 24.05.11.
http www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-A-2011-105-02
234988 - PENSOLAR MIZQUITILLAS 19 SOCIEDAD LIMITADA.
Nombramientos. Apoderado: RODENAS RIVERA PEDRO. Datos registrales. T 835, L 599, F 182, S 8, H AB 16478, I/A 7
24.05.11.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958