Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 13/12/2011 - Empresarios
Versión en texto ¿Qué es?Dateas es un sitio independiente no afiliado a entidades gubernamentales. La fuente de los documentos PDF aquí publicados es la entidad gubernamental indicada en cada uno de ellos. Las versiones en texto son transcripciones no oficiales que realizamos para facilitar el acceso y la búsqueda de información, pero pueden contener errores o no estar completas.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Empresarios
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 234
Martes 13 de diciembre de 2011
Pág. 69460
SECCIÓN PRIMERA
Empresarios Actos inscritos ALBACETE
492945 - AUTO FAMIDELMAR SOCIEDAD LIMITADA.
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: LOPEZ HERNANDEZ JOSE MANUEL. Datos registrales. T 776, L 540, F 51, S 8, H AB 13490, I/A
4 4.11.11.
492946 - RAINBOW TRADING SOCIEDAD LIMITADA.
Ceses/Dimisiones. Liquidador: ROMERO NOVOA MARIA TERESA. Adm. Unico: ROMERO NOVOA MARIA TERESA.
Nombramientos. Liquidador: ROMERO NOVOA MARIA TERESA. Disolución. Voluntaria. Extinción. Datos registrales. T 725, L
489, F 60, S 8, H AB 11130, I/A 4 30.11.11.
492947 - M A DISTRIBUCIONES SOCIEDAD ANONIMA.
Nombramientos. Apoderado: MORAL VERDEJO MARIA JULIANA. Datos registrales. T 277, L 41, F 148, S 8, H AB 1715, I/A 10
30.11.11.
492948 - AGUIGAME SL.
Ampliación de capital. Capital: 249.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 429.000,00 Euros. Datos registrales. T 906, L 670, F 161, S
8, H AB 22029, I/A 3 30.11.11.
492949 - SANAGUAS OBRA CIVIL SOCIEDAD ANONIMA.
Reelecciones. Consejero: VALERO MUNERA JESUS. Presidente: VALERO MUNERA JESUS. Consejero: VALERO MUNERA
GERMAN. Secretario: VALERO MUNERA GERMAN. Consejero: VALERO MUNERA JUAN. Cons.Del.Man: VALERO MUNERA
GERMAN;VALERO MUNERA JESUS;VALERO MUNERA JUAN. Datos registrales. T 844, L 608, F 16, S 8, H AB 9010, I/A 8
30.11.11.
492950 - SOCIEDAD GENERAL DE PATRIMONIOS Y EXPLOTACIONES SOCIEDAD LIMITADA.
Cambio de domicilio social. C/ INFANTE JAIME 27 VILLARROBLEDO. Datos registrales. T 743, L 507, F 193, S 8, H AB 11902, I/A 3 30.11.11.
492951 - M & M 500 SOCIEDAD LIMITADA.
Cambio de domicilio social. C/ INFANTE JAIME 27 VILLARROBLEDO. Datos registrales. T 828, L 592, F 7, S 8, H AB 9054, I/A
6 30.11.11.
492952 - INSTALACIONES ELECTRO-MECANICAS CASTILLA SOCIEDAD LIMITADA.
Cambio de domicilio social. C/ INFANTE JAIME 27 VILLARROBLEDO. Datos registrales. T 731, L 495, F 40, S 8, H AB 11360, I/A 4 30.11.11.
492954 - PRIUS ENERGY SOCIEDAD LIMITADA.
Ampliacion del objeto social. b La prestación de servicios, tales como estudios, informes, análisis, asesoramiento, proyectos, cálculos, trabajos de ingenieria, investigación, desarrollo y puesta a punto, tanto para empresas como para particulares y organismos públicos, de toda clase, de proyectos incluidos las energías renovab. Datos registrales. T 900, L 664, F 51, S 8, H AB 16329, I/A 7
30.11.11.
492955 - BODEGAS Y ACTIVIDADES AGRICOLAS SOCIEDAD LIMITADA.
Ceses/Dimisiones. Consejero: SANCHEZ-MULITERNO GARCIA JUAN. Revocaciones. Apoderado: SANCHEZ-MULITERNO
GARCIA JUAN. Nombramientos. Consejero: SANCHEZ-MULITERNO GARCIA BEATRIZ. Co.De.Ma.So: SANCHEZ-MULITERNO
GARCIA BEATRIZ. Datos registrales. T 724, L 488, F 144, S 8, H AB 6243, I/A 18 30.11.11.
492956 - ALBACETE BULEVAR SOCIEDAD LIMITADA EN LIQUIDACION.
Ceses/Dimisiones. Consejero: ZAFRILLA SALAS CRISTOBAL;LOPEZ RUBIO SANTIAGO;CANO ROSELL ULPIANO. Presidente:
cve: BORME-A-2011-234-02
492953 - INSTALACIONES ELECTRO-MECANICAS CASTILLA SOCIEDAD LIMITADA.
Nombramientos. Apoderado: RIOS RUIZ ANGEL PEDRO. Datos registrales. T 912, L 676, F 26, S 8, H AB 11360, I/A 5 30.11.11.